Making of Modern Law : Primary Sources (1620-1926)
Das Produkt ist der letzte Teil der Serie und stellt auf 1.850.000 Seiten 1.740 Titel mit Quellenmaterial der US-amerikanischen Rechtsgeschichte bereit. Die Materialien entstammen mehrheitlich der Lillian Goldman Law Library der Universität Yale. Die Datenbank beinhaltet Texte aus verfassungsgebenden Versammlungen (u. a. Protokolle, Berichte), Stadtrechte und frühe Gesetzgebung der Bundesstaaten, historische juristische Nachschlagewerke sowie der Primary Source Microfilm-Sammlung Published Records of the American Colonies entnommene Aufzeichnungen aus der Kolonialzeit. Dieses für die Rechts-, Kultur- und Sozialgeschichte des anglo-amerikanischen Kulturraums wichtige digitale Archiv ist im Volltext recherchierbar. Part I, II und III sind bereits als Nationallizenz vorhanden.
(Nutzungsbedingungen)Körperschaften
- New York (State)  26
- New York (State) Constitutional Convention ((1894))  8
- New York (State) Board of Statutory Consolidation  7
- New York (State) Constitutional Convention ((1915))  4
- Albany (N.Y.)  3
- Albany (N.Y.) Common Council  3
- Charles R. and George Webster (Firm)  2
- United States  2
- New York (State) Constitutional Convention ((1821))  1
- New York (State) Constitutional Convention ((1846))  1
- New York (State) Secretary's Office  1
Personen
- O'Callaghan, E. B.  11
- Brodhead, John Romeyn  10
- Butler, Benjamin Franklin  9
- Duer, John  9
- Spencer, John Canfield  9
- ,   5
- Fitch, Charles Elliott  5
- Steele, William H.  5
- Cothran, George W.  3
- Flagg, Azariah Cutting  3
- Parker, Amasa Junius  3
- Wade, Edward  3
- Wolford, George  3
- Denio, Hiram  2
- Grantham, Edwin L.  2
- Morgan, Christopher  2
- O'callaghan, E. B.  2
- Tracy, William  2
- Van Ness, William Peter  2
- Wadhams, Frederick E.  2
- Woodworth, John  2
- Attree, William H.  1
- Bishop, William G.  1
- Carter, Nathaniel Hazeltine  1
- Chester, Alden  1
- Choate, Joseph Hodges  1
- Clark, Charles Hopkins  1
- Conant, A. G.  1
- Cook, John Thomas  1
- Dennin, William W.  1
- Edmonds, John Worth  1
- Fernow, B.  1
- Haigh, H. M.  1
- Hillhouse, James  1
- Merrill, John J.  1
- O'CAllaghan, E. B.  1
- Roberts, Charles O.  1
- Rodenbeck, Adolph Julius  1
- Rudd, William P.  1
- Stone, William Leete  1
Erscheinungsort
Verlage
- Weed, Parsons And Company  12
- J.B. Lyon Co., State Printers  9
- Argus Co., printers  8
- Printed by Packard and Van Benthuysen  8
- James B. Lyon  6
- Argus Co  5
- J.B. Lyon Co., printers  5
- Banks & Bros  4
- Banks & Brothers  4
- Gould, Banks & Co  3
- H. B. Parsons  3
- Printed and published by H.C. Southwick & co., no. 94, State-street  3
- Printed by Charles R. and George Webster  3
- J. B. Lyon Company, State Printers  2
- Weare C. Little and Co.  2
- Weed, Parsons & Co.  2
- Weed, Parsons and Company  2
- Argus Company  1
- Carroll and Cook, Printers to the Convention  1
- Charles Van Benthuysen  1
- E. and E. Horsford  1
- H.B. Parsons  1
- J. B. Lyon Company, Printers  1
- James B. Lyon, Publisher  1
- Printed at the office of the Evening Atlas  1
- Printed by A. Southwick  1
- Weare C. Little & Co.  1
- Weare C. Little & Company  1
- Weed, Parsons & Company, Printers to the Convention  1
- Weed, Parsons And Company.  1
- Weed, Parsons and Co.  1
- Weed, Parsons and Co., Printers  1
Erscheinungsdatum
- 1802  3
- 1813  3
- 1821  1
- 1829  4
- 1836  4
- 1838  1
- 1846  5
- 1848  1
- 1849  1
- 1850  1
- 1851  1
- 1852  3
- 1853  1
- 1854  1
- 1855  3
- 1856  2
- 1857  1
- 1858  2
- 1859  4
- 1861  1
- 1867  1
- 1868  1
- 1869  1
- 1871  1
- 1872  1
- 1875  4
- 1877  1
- 1881  1
- 1882  2
- 1887  1
- 1894  8
- 1895  2
- 1896  2
- 1897  1
- 1900  6
- 1901  3
- 1909  8
- 1910  2
- 1915  1
- 1916  5
- 1920  1
Sprache
-
lock
-
lock
-
lock
-
lock
-
lock
-
lock
-
lock
-
lock
-
lock
-
lock
-
lock
-
lock
-
lock
-
lock
-
lock